-
PROGENITOR LABS LIMITED - 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07155558
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 New Street Square
- London
- EC4A 3TW 5 New Street Square, London, EC4A 3TW UK
Management
- Geschäftsführung
- CHOO, Evgenios
- Prokuristen
- TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.02.2010
- Alter der Firma 2010-02-12 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Evgenios Choo
- Plasticell Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PLASTICELL THERAPEUTICS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-26
- Letzte Einreichung: 2020-02-12
-
PROGENITOR LABS LIMITED Firmenbeschreibung
- PROGENITOR LABS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07155558. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.02.2010 registriert. PROGENITOR LABS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PLASTICELL THERAPEUTICS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 5 New Street Square erreicht werden.
Jetzt sichern PROGENITOR LABS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Progenitor Labs Limited - 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, Grossbritannien
- 2010-02-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROGENITOR LABS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-11-09) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-11-05) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-14) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-14) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-08) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-07) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-17) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-24) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-02) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-02-16) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-09) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-05-12) - SH08
-
resolution (2014-04-09) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-20) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-03-20) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-11) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-18) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-16) - AP01
-
resolution (2013-03-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-10) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-03-12) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-01-18) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2011-01-18) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2011-01-18) - SH08
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-01-31) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2011-03-03) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-03-03) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
resolution (2010-09-24) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2010-09-24) - SH02
-
termination-director-company-with-name (2010-09-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-13) - AP01
-
incorporation-company (2010-02-12) - NEWINC