-
STANLEY BRAGG ARCHITECTS LTD - Pappus House Tollgate West, Stanway, Colchester, CO3 8AQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07154929
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Pappus House Tollgate West
- Stanway
- Colchester
- CO3 8AQ
- England Pappus House Tollgate West, Stanway, Colchester, CO3 8AQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CULLEN, Andrew Stephen
- ROE, Graeme
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.02.2010
- Alter der Firma 2010-02-11 14 Jahre
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Graeme Roe
- Mr Andrew Stephen Cullen
- Mr Graeme Roe
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ZENCRAFT LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-25
- Letzte Einreichung: 2020-02-11
-
STANLEY BRAGG ARCHITECTS LTD Firmenbeschreibung
- STANLEY BRAGG ARCHITECTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07154929. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.02.2010 registriert. STANLEY BRAGG ARCHITECTS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ZENCRAFT LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Pappus House Tollgate West erreicht werden.
Jetzt sichern STANLEY BRAGG ARCHITECTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stanley Bragg Architects Ltd - Pappus House Tollgate West, Stanway, Colchester, CO3 8AQ, Grossbritannien
- 2010-02-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STANLEY BRAGG ARCHITECTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-09) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-14) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-14) - PSC07
-
legacy (2018-11-27) - RP04CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-21) - TM01
-
resolution (2017-06-28) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-22) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-08-21) - SH03
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-26) - AA
-
resolution (2016-07-27) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-30) - CH01
-
capital-cancellation-shares (2016-03-15) - SH06
-
resolution (2016-03-15) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-11) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-07-27) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-09) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-23) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-07-20) - AA01
-
capital-allotment-shares (2011-07-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-20) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-21) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-08) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-02-24) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2010-02-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-04) - AP01
-
change-of-name-notice (2010-05-13) - CONNOT
-
resolution (2010-05-13) - RESOLUTIONS
-
resolution (2010-05-26) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-07) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-07-07) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2010-06-10) - CERTNM
-
incorporation-company (2010-02-11) - NEWINC