-
BLACKFEN MOTORIST CENTRE LTD - Adams & Moore House, Instone Road, Dartford, DA1 2AG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07145851
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Adams & Moore House
- Instone Road
- Dartford
- DA1 2AG Adams & Moore House, Instone Road, Dartford, DA1 2AG UK
Management
- Geschäftsführung
- RUMP, Gary Derrick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2010
- Alter der Firma 2010-02-04 14 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gary Derrick Rump
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-11-30
- Letzte Einreichung: 2023-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-04
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-02-18
- Letzte Einreichung: 2024-02-04
-
BLACKFEN MOTORIST CENTRE LTD Firmenbeschreibung
- BLACKFEN MOTORIST CENTRE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07145851. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.02.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Adams & Moore House erreicht werden.
Jetzt sichern BLACKFEN MOTORIST CENTRE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blackfen Motorist Centre Ltd - Adams & Moore House, Instone Road, Dartford, DA1 2AG, Grossbritannien
- 2010-02-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLACKFEN MOTORIST CENTRE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-updates (2024-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-02-10) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-02-10) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-02-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-13) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-24) - PSC04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-21) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-24) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-22) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-28) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-12-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-02-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-02-05) - TM01
-
incorporation-company (2010-02-04) - NEWINC