-
ONSITE MIDLANDS LIMITED - Two, Snow Hill, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07145667
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Two
- Snow Hill
- Birmingham
- B4 6GA Two, Snow Hill, Birmingham, B4 6GA UK
Management
- Geschäftsführung
- GRANTHAM, Anne Kay
- HOMER, Craig Stuart
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2010
- Gelöscht am:
- 2020-04-09
- SIC/NACE
- 78200
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ONSITE CONSTRUCTION RECRUITMENT (MIDLANDS) LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-11-30
- Letzte Einreichung: 2016-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-04
-
ONSITE MIDLANDS LIMITED Firmenbeschreibung
- ONSITE MIDLANDS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07145667. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.02.2010 registriert. ONSITE MIDLANDS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ONSITE CONSTRUCTION RECRUITMENT (MIDLANDS) LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Two erreicht werden.
Jetzt sichern ONSITE MIDLANDS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Onsite Midlands Limited - Two, Snow Hill, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ONSITE MIDLANDS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-04-09) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-01-09) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-04-05) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-28) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-02-08) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2017-02-08) - 4.20
-
resolution (2017-02-08) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-09-29) - 600
-
liquidation-miscellaneous (2017-11-09) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2017-09-19) - LIQ10
-
liquidation-resolution-miscellaneous (2017-02-08) - LIQ MISC RES
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-13) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-29) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-07-30) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-07) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2014-05-06) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-05-08) - DISS40
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-03-06) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2013-03-05) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-04) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2012-05-01) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-05-05) - DISS40
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-04) - AA
-
legacy (2011-01-15) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-06) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-01-02) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-08-09) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2010-06-01) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2010-06-01) - CONNOT
-
incorporation-company (2010-02-04) - NEWINC