-
FIZZ DIGITAL LIMITED - 9-11 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 3LU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07130492
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9-11 Stratford Road
- Shirley
- Solihull
- B90 3LU
- England 9-11 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 3LU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MCGILL, Robert Bryce
- MCGILL, Adam
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.01.2010
- Alter der Firma 2010-01-20 14 Jahre
- SIC/NACE
- 58190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Adam Mcgill
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-10
- Letzte Einreichung: 2023-01-27
-
FIZZ DIGITAL LIMITED Firmenbeschreibung
- FIZZ DIGITAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07130492. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.01.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 9-11 Stratford Road erreicht werden.
Jetzt sichern FIZZ DIGITAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fizz Digital Limited - 9-11 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 3LU, Grossbritannien
- 2010-01-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FIZZ DIGITAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-11-12) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-11-12) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2023-01-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-03-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-08) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-02) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-06-08) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-18) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-08) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-07-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-15) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-26) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-01) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-09-05) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-10-06) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-02-13) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-02) - AP01
-
resolution (2010-02-15) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2010-01-20) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2010-03-02) - SH01
-
resolution (2010-03-04) - RESOLUTIONS