-
COALT CONTRACT SERVICES LIMITED - Townshend House, Crown Road, Norwich, NR1 3DT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07129004
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Townshend House
- Crown Road
- Norwich
- NR1 3DT Townshend House, Crown Road, Norwich, NR1 3DT UK
Management
- Geschäftsführung
- DOBSON, Michael John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.01.2010
- Gelöscht am:
- 2020-11-15
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Wiliam John Davidson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- TECHNICAL CONTRACT SERVICES LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2016-01-31
-
COALT CONTRACT SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- COALT CONTRACT SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07129004. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 19.01.2010 registriert. COALT CONTRACT SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TECHNICAL CONTRACT SERVICES LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Townshend House erreicht werden.
Jetzt sichern COALT CONTRACT SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Coalt Contract Services Limited - Townshend House, Crown Road, Norwich, NR1 3DT, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COALT CONTRACT SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-11-15) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-return-final-meeting (2020-08-15) - WU15
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2019-08-02) - WU07
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-28) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2018-06-26) - WU04
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2018-06-20) - COCOMP
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2018-06-06) - COCOMP
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-06-01) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-15) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-notice-compulsory (2017-01-03) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-07) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-30) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-02) - AP01
-
resolution (2017-05-02) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-06) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-06) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-08) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-09) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-09-18) - DISS40
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-17) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-17) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-07-28) - CERTNM
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-04-02) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2015-02-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-06-07) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-06) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2014-05-20) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-06-21) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-06-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-04-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-19) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2012-06-22) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-10-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-01-19) - NEWINC