-
THE PACE GALLERY LIMITED - 5 Hanover Square, London, W1S 1HQ, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07117911
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Hanover Square
- London
- W1S 1HQ
- England 5 Hanover Square, London, W1S 1HQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GLIMCHER, Marc Cooper
- HARNDEN, Christopher Walton
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.01.2010
- Alter der Firma 2010-01-06 14 Jahre
- SIC/NACE
- 47781
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Arne Glimcher
- Marc Cooper Glimcher
- Arne Glimcher
- Marc Cooper Glimcher
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- DMWSL 630 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-18
- Letzte Einreichung: 2021-01-04
-
THE PACE GALLERY LIMITED Firmenbeschreibung
- THE PACE GALLERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07117911. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.01.2010 registriert. THE PACE GALLERY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DMWSL 630 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47781" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 5 Hanover Square erreicht werden.
Jetzt sichern THE PACE GALLERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Pace Gallery Limited - 5 Hanover Square, London, W1S 1HQ, England, Grossbritannien
- 2010-01-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE PACE GALLERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-10-28) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-06-09) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-08-25) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-09-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-08) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-05-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-08) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-08) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-22) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-05-17) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-08-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-04) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-09) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2015-12-22) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-08-20) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-19) - AR01
-
miscellaneous (2014-10-20) - MISC
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-08-21) - AA
-
change-sail-address-company (2014-02-19) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-19) - CH01
-
move-registers-to-sail-company (2014-02-19) - AD03
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-group (2013-11-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-19) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-10-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-12) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-02-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-18) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-14) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-27) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-10-05) - AA
-
legacy (2011-08-04) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-03-10) - TM01
-
incorporation-company (2010-01-06) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2010-03-12) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-03-10) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-03-10) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-03-10) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-10) - AP01