• UK
  • PROMPT SUPPLIERS LTD - Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
07114014
Firmenstatus
EINGETRAGEN
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Griffins Tavistock House South
Tavistock Square
London
WC1H 9LG
Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG UK

Management

Geschäftsführung
MALHAN, Anil Kumar

Firmendetails

Geschäftszweig
ltd
Gründungsdatum
30.12.2009
Gelöscht am:
2016-04-05
SIC/NACE
14132

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
liquidation
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit: 2013-09-30
Letzte Einreichung: 2011-12-31
lezte Bilanzhinterlegung
2011-12-30
Jahresmeldung
Fälligkeit: 2017-01-13
Letzte Einreichung:

PROMPT SUPPLIERS LTD Firmenbeschreibung

PROMPT SUPPLIERS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07114014. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "14132" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.12.2011.Die Firma kann schriftlich über Griffins Tavistock House South erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern PROMPT SUPPLIERS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: Prompt Suppliers Ltd - Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG, Grossbritannien

2009-12-30 14 Jahre

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROMPT SUPPLIERS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-05-24) - LIQ14

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-12) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-16) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-18) - 4.68

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-14) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-10-27) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-05) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-05-31) - 600

    In den Warenkorb
     
  • restoration-order-of-court (2017-05-23) - AC92

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-court-order-miscellaneous (2017-05-26) - LIQ MISC OC

    In den Warenkorb
     
  • gazette-dissolved-liquidation (2016-04-05) - GAZ2

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2016-01-05) - 4.72

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-11-04) - 4.68

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2014-08-28) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-02) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2014-08-28) - 4.20

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2014-08-28) - 600

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-voluntary (2014-08-26) - GAZ1(A)

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsary (2014-01-07) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-02-13) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2013-06-25) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsary (2013-04-30) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2013-01-26) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-24) - AA

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsary (2013-01-22) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsary (2012-01-10) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2012-01-11) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-02) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-18) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name (2012-07-05) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name (2012-07-05) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2011-05-21) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-20) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsary (2011-04-26) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2009-12-30) - NEWINC

    In den Warenkorb
     

expand_less