-
AUCTION HOUSE WEST YORKSHIRE LIMITED - Leigh House, 28-32 St Pauls Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07100384
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Leigh House
- 28-32 St Pauls Street
- Leeds
- West Yorkshire
- LS1 2JT Leigh House, 28-32 St Pauls Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 2JT UK
Management
- Geschäftsführung
- ANDREWS, Michael Christopher
- MANNING, Russell John
- PANK, David
- MANNING, Mark Brian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-10 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Russell John Manning
- Mr David Pank
- Mr David Pank
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MANNING STAINTON AUCTION HOUSE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-24
- Letzte Einreichung: 2022-12-10
-
AUCTION HOUSE WEST YORKSHIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- AUCTION HOUSE WEST YORKSHIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07100384. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.12.2009 registriert. AUCTION HOUSE WEST YORKSHIRE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MANNING STAINTON AUCTION HOUSE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Leigh House erreicht werden.
Jetzt sichern AUCTION HOUSE WEST YORKSHIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Auction House West Yorkshire Limited - Leigh House, 28-32 St Pauls Street, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
- 2009-12-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AUCTION HOUSE WEST YORKSHIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-14) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-08-24) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-14) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-04-03) - SH02
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-04) - AR01
-
resolution (2013-04-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-02-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
memorandum-articles (2011-10-13) - MEM/ARTS
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-09) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2011-08-30) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-08-30) - CONNOT
-
capital-alter-shares-subdivision (2011-07-12) - SH02
-
resolution (2011-07-12) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-10) - AD01
-
resolution (2011-04-20) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2011-04-20) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-01-16) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-10) - NEWINC