-
SOLARLEC PV SOLUTIONS LIMITED - 20 Roundhouse Court South Rings Business Park, Bamber Bridge, Preston, Lancashire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07088524
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 20 Roundhouse Court South Rings Business Park
- Bamber Bridge
- Preston
- Lancashire
- PR5 6DA 20 Roundhouse Court South Rings Business Park, Bamber Bridge, Preston, Lancashire, PR5 6DA UK
Management
- Geschäftsführung
- KEIGHLEY, Nicholas Derrick
- ROWBOTTOM, Gerard Martin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.11.2009
- Alter der Firma 2009-11-27 14 Jahre
- SIC/NACE
- 43210
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-11-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-12-11
- Letzte Einreichung:
-
SOLARLEC PV SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- SOLARLEC PV SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07088524. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.11.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43210" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2014 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.11.2015.Die Firma kann schriftlich über 20 Roundhouse Court South Rings Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern SOLARLEC PV SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Solarlec Pv Solutions Limited - 20 Roundhouse Court South Rings Business Park, Bamber Bridge, Preston, Lancashire, Grossbritannien
- 2009-11-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOLARLEC PV SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-08-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-07-17) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-17) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-08-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-08-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-08-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-disclaimer-notice (2016-07-22) - F10.2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-06-24) - 600
-
resolution (2016-06-24) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-15) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-21) - MR01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-06-24) - 4.20
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-medium (2015-07-06) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-08-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-29) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-04-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-25) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-15) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-08) - AA
-
legacy (2011-01-15) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-04-19) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-04-19) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-02) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-11-16) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
termination-director-company-with-name (2009-12-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-04) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-12-04) - AD01
-
incorporation-company (2009-11-27) - NEWINC