-
STORYTIME MAGAZINE LTD - 64 Southwark Bridge Road, London, SE1 0AS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07086169
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 64 Southwark Bridge Road
- London
- SE1 0AS 64 Southwark Bridge Road, London, SE1 0AS UK
Management
- Geschäftsführung
- COATHUP, Leslie
- MAZZOCCO SKANTZE, Luciana
- COLLINS, Michael Alan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.11.2009
- Alter der Firma 2009-11-25 14 Jahre
- SIC/NACE
- 58190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Luciana Mazzocco Skantze
- Leslie Coathup
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- LUMA CREATIVE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-29
- Letzte Einreichung: 2023-04-15
-
STORYTIME MAGAZINE LTD Firmenbeschreibung
- STORYTIME MAGAZINE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07086169. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.11.2009 registriert. STORYTIME MAGAZINE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LUMA CREATIVE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58190" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 64 Southwark Bridge Road erreicht werden.
Jetzt sichern STORYTIME MAGAZINE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Storytime Magazine Ltd - 64 Southwark Bridge Road, London, SE1 0AS, Grossbritannien
- 2009-11-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STORYTIME MAGAZINE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-04-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-08-22) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-08-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
capital-allotment-shares (2021-01-25) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-07) - AP01
-
memorandum-articles (2021-02-18) - MA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-06) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-07-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-23) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-23) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-23) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-25) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-14) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-08) - CH01
-
resolution (2019-11-28) - RESOLUTIONS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-12) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-12) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-12) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-08-08) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-18) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-15) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-22) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-07) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-07) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-03-07) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-14) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-17) - AR01
-
capital-return-purchase-own-shares (2010-02-05) - SH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-01-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-11-25) - NEWINC