-
STICKLANDS LIMITED - 4 High Street, Alton, Hampshire, GU34 1BU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07085395
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 High Street
- Alton
- Hampshire
- GU34 1BU 4 High Street, Alton, Hampshire, GU34 1BU UK
Management
- Geschäftsführung
- JOYCE, Paula
- KENSETT, Amy Claire
- SANDERS, David Andrew
- SHARPE, Philip James
- WRIGHT, Paul Edward Henry
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.11.2009
- Alter der Firma 2009-11-24 14 Jahre
- SIC/NACE
- 69201
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- 300 QUARRY STREET LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-14
- Letzte Einreichung: 2021-05-31
-
STICKLANDS LIMITED Firmenbeschreibung
- STICKLANDS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07085395. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.11.2009 registriert. STICKLANDS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 300 QUARRY STREET LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 4 High Street erreicht werden.
Jetzt sichern STICKLANDS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sticklands Limited - 4 High Street, Alton, Hampshire, GU34 1BU, Grossbritannien
- 2009-11-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STICKLANDS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-10-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-14) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2021-09-22) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-20) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2021-09-20) - SH06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-02) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-25) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-19) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-04-28) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-26) - AR01
-
second-filing-of-form-with-form-type (2013-06-21) - RP04
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-12) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-24) - AP01
-
capital-allotment-shares (2012-04-24) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2012-04-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-03-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-31) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-05-31) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-23) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
certificate-change-of-name-company (2010-07-02) - CERTNM
-
capital-alter-shares-subdivision (2010-05-26) - SH02
-
resolution (2010-05-26) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-05-25) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-05-25) - AD01
-
change-of-name-notice (2010-05-19) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-11-24) - NEWINC