-
PROJECT AF LIMITED - Suite 501 Unit 2a 94 Wycliffe Road, Northampton, NN1 5JF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07082810
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 501 Unit 2a 94 Wycliffe Road
- Northampton
- NN1 5JF Suite 501 Unit 2a 94 Wycliffe Road, Northampton, NN1 5JF UK
Management
- Geschäftsführung
- CHANES, Amanda Sara
- STIMLER, Martin
- STIMLER, Steven
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.11.2009
- Alter der Firma 2009-11-20 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Amanda Sara Chanes
- Mr Martin Stimler
- Mr Steven Stimler
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-04
- Letzte Einreichung: 2023-11-20
-
PROJECT AF LIMITED Firmenbeschreibung
- PROJECT AF LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07082810. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.11.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite 501 Unit 2A 94 Wycliffe Road erreicht werden.
Jetzt sichern PROJECT AF LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Project Af Limited - Suite 501 Unit 2a 94 Wycliffe Road, Northampton, NN1 5JF, Grossbritannien
- 2009-11-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROJECT AF LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-01-04) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-07-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-29) - CS01
-
resolution (2023-12-10) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-12-10) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2023-12-10) - LIQ01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-12-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-06) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-09-09) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-03) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-20) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-02) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-secretary-company-with-name (2011-12-19) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-16) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-16) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-08-24) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-02-11) - AP03
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-11-20) - NEWINC