-
W P A BUSINESS SERVICES LIMITED - 26 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07061190
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 26 Grosvenor Street
- Mayfair
- London
- W1K 4QW 26 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QW UK
Management
- Geschäftsführung
- HEWSON, Nicole
- MITCHELL, Natalie
- Prokuristen
- WILTON CORPORATE SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-29 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Wilton Uk (Group) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-12
- Letzte Einreichung: 2020-10-29
-
W P A BUSINESS SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- W P A BUSINESS SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07061190. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 26 Grosvenor Street erreicht werden.
Jetzt sichern W P A BUSINESS SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: W P A Business Services Limited - 26 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QW, Grossbritannien
- 2009-10-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu W P A BUSINESS SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-18) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-09) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-29) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-29) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-29) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-27) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-05-05) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-04-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-01) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-31) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-31) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-31) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-28) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-04-19) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2016-04-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-02) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-24) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-06-23) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-10) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2015-05-05) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-13) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-08-02) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-05-06) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name (2014-01-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-12-20) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-01-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-20) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-07-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-09) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-04-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-26) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-10-29) - NEWINC