-
CARS 2 DELIVER LIMITED - The Town Hall 83 Burnley Road, Padiham, Burnley, Lancashire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07054721
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Town Hall 83 Burnley Road
- Padiham
- Burnley
- Lancashire
- BB12 8BS The Town Hall 83 Burnley Road, Padiham, Burnley, Lancashire, BB12 8BS UK
Management
- Geschäftsführung
- KIDD, Richard Harold
- Prokuristen
- JEMMETT FOX COMPANY SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.10.2009
- Gelöscht am:
- 2024-01-27
- SIC/NACE
- 49410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard Harold Kidd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-04
- Letzte Einreichung: 2019-10-23
-
CARS 2 DELIVER LIMITED Firmenbeschreibung
- CARS 2 DELIVER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07054721. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49410" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.10.2012.Die Firma kann schriftlich über The Town Hall 83 Burnley Road erreicht werden.
Jetzt sichern CARS 2 DELIVER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cars 2 Deliver Limited - The Town Hall 83 Burnley Road, Padiham, Burnley, Lancashire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CARS 2 DELIVER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-liquidation (2024-01-27) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-10-27) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-10-27) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-01) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-09-27) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-09-18) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-18) - AD01
-
resolution (2020-09-18) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-09-18) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-30) - AA
-
legacy (2012-06-19) - MG01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-11-13) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-06-01) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2012-05-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-01-10) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2012-11-26) - TM02
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-07-13) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-07-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-24) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-14) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-07-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-12-01) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-12-09) - AD01
-
incorporation-company (2009-10-23) - NEWINC