-
VIPRINT LIMITED - Olympia House, Armitage Road, London, NW11 8RQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07053431
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Olympia House
- Armitage Road
- London
- NW11 8RQ Olympia House, Armitage Road, London, NW11 8RQ UK
Management
- Geschäftsführung
- PORT, Anthony Nigel
- STERN, Gary Louis
- Prokuristen
- COHEN, Sandra Diane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.10.2009
- Gelöscht am:
- 2017-12-26
- SIC/NACE
- 82990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-11-04
- Letzte Einreichung:
-
VIPRINT LIMITED Firmenbeschreibung
- VIPRINT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07053431. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2014 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Olympia House erreicht werden.
Jetzt sichern VIPRINT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Viprint Limited - Olympia House, Armitage Road, London, NW11 8RQ, Grossbritannien
- 2009-10-22
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VIPRINT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
order-of-court-restoration-previously-creditors-voluntary-liquidation (2018-09-03) - REST-CVL
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-dissolved-liquidation (2017-12-26) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2017-09-26) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-09-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-24) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-08-18) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-08-18) - 600
-
resolution (2016-08-18) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-22) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-12-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-02-26) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-02-19) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-02-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-11-25) - AP01
-
capital-allotment-shares (2009-11-17) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2009-11-16) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2009-11-16) - TM02
-
incorporation-company (2009-10-22) - NEWINC