-
IN 2 TILES LIMITED - 4 Stakes Hill Road, Waterlooville, Hampshire, PO7 7HY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07051076
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Stakes Hill Road
- Waterlooville
- Hampshire
- PO7 7HY 4 Stakes Hill Road, Waterlooville, Hampshire, PO7 7HY UK
Management
- Geschäftsführung
- BERRY, Damian Luke
- ROBINSON, Jacques Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-20 14 Jahre
- SIC/NACE
- 46130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Brian Elkins
- Mr Jacques Peter Robinson
- Mr Damian Luke Berry
- -
- Mr. Jacques Peter Robinson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- 2 TILES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-03
- Letzte Einreichung: 2022-10-20
-
IN 2 TILES LIMITED Firmenbeschreibung
- IN 2 TILES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07051076. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.10.2009 registriert. IN 2 TILES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 2 TILES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46130" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 4 Stakes Hill Road erreicht werden.
Jetzt sichern IN 2 TILES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: In 2 Tiles Limited - 4 Stakes Hill Road, Waterlooville, Hampshire, PO7 7HY, Grossbritannien
- 2009-10-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IN 2 TILES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-07-29) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2023-04-04) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-05-11) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-28) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-09) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-01-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-02) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-23) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-01-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-02-05) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-17) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-11-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-06) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-06) - AD01
-
capital-allotment-shares (2012-11-09) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-17) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-07-05) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-06-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-10-20) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2009-11-25) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2009-11-25) - CONNOT