-
SUPPLY PROJECT SOLUTIONS LIMITED - 170 Llanederyn Road, Cardiff, CF23 9EA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07044603
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 170 Llanederyn Road
- Cardiff
- CF23 9EA 170 Llanederyn Road, Cardiff, CF23 9EA UK
Management
- Geschäftsführung
- SMITH, Linda Jane
- DAVISON-SEBRY, Cherrie Belinda
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.10.2009
- Alter der Firma 2009-10-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 46190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Persondy Properties Ltd
- Mr Peter Vivian Smith
- Mrs Cherrie Belinda Davison-Sebry
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-29
- Letzte Einreichung: 2021-10-15
-
SUPPLY PROJECT SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- SUPPLY PROJECT SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07044603. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.10.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 170 Llanederyn Road erreicht werden.
Jetzt sichern SUPPLY PROJECT SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Supply Project Solutions Limited - 170 Llanederyn Road, Cardiff, CF23 9EA, Grossbritannien
- 2009-10-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SUPPLY PROJECT SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-23) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-05-05) - PSC02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-05-05) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-11) - PSC05
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-10-11) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-11) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-08-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-10-08) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-10-08) - PSC01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-01) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-12) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-08) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-19) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-10-21) - SH01
-
resolution (2019-10-21) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-07-26) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-17) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-28) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-03) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-28) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-18) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-16) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-17) - AR01
-
capital-allotment-shares (2011-07-18) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-11-06) - AP01
-
incorporation-company (2009-10-15) - NEWINC