-
MY DEBT LIFELINE (UK) LIMITED - 2 Pacific Court, Atlantic Street, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07034880
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Pacific Court
- Atlantic Street
- Altrincham
- Cheshire
- WA14 5BJ 2 Pacific Court, Atlantic Street, Altrincham, Cheshire, WA14 5BJ UK
Management
- Geschäftsführung
- GOLDSMITH, Lee Mitchell
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.09.2009
- Gelöscht am:
- 2021-07-12
- SIC/NACE
- 64999
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-04-28
- Letzte Einreichung: 2015-07-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-10-16
- Letzte Einreichung:
-
MY DEBT LIFELINE (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- MY DEBT LIFELINE (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07034880. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 30.09.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Pacific Court erreicht werden.
Jetzt sichern MY DEBT LIFELINE (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: My Debt Lifeline (Uk) Limited - 2 Pacific Court, Atlantic Street, Altrincham, Cheshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MY DEBT LIFELINE (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2021-04-12) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-10-08) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-23) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-10-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-09-30) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-29) - AA
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2015-08-13) - 4.70
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-08-13) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-14) - AD01
-
resolution (2015-08-25) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-10-21) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-22) - AA
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2015-08-25) - 4.70
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-27) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-01) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-07-30) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-11-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-22) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-13) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-24) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2012-11-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-21) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-12-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-27) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-06-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-09-30) - NEWINC