-
MAG PLUMBING AND HEATING LIMITED - 9, Home Farm, St Johns Road St. Johns Road, Hedge End, Southampton, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07013808
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9
- Home Farm, St Johns Road St. Johns Road
- Hedge End
- Southampton
- SO30 4DF
- England 9, Home Farm, St Johns Road St. Johns Road, Hedge End, Southampton, SO30 4DF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WARD, Christopher James
- Prokuristen
- WARD, Charlotte Elyse
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.09.2009
- Alter der Firma 2009-09-09 14 Jahre
- SIC/NACE
- 43220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Christopher James Ward
- Mrs Charlotte Elyse Ward
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SEATECH CIVIL AND MARINE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-06
- Letzte Einreichung: 2020-05-23
-
MAG PLUMBING AND HEATING LIMITED Firmenbeschreibung
- MAG PLUMBING AND HEATING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07013808. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.09.2009 registriert. MAG PLUMBING AND HEATING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SEATECH CIVIL AND MARINE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 9 erreicht werden.
Jetzt sichern MAG PLUMBING AND HEATING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mag Plumbing And Heating Limited - 9, Home Farm, St Johns Road St. Johns Road, Hedge End, Southampton, Grossbritannien
- 2009-09-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MAG PLUMBING AND HEATING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-09) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-11-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-09) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-02-09) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-09) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-10-06) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2014-02-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-08) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-12) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-12) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-28) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-03-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-05) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-10-05) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-12-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-10-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-29) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2010-03-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-09-09) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2009-12-01) - AA01