• UK
  • PEOVER INNS LIMITED - Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
07007704
Firmenstatus
EINGETRAGEN
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Griffins Tavistock House South
Tavistock Square
London
WC1H 9LG
Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG UK

Management

Geschäftsführung
ARMSTRONG, Richard
Prokuristen
-

Firmendetails

Geschäftszweig
ltd
Gründungsdatum
03.09.2009
Alter der Firma
2009-09-03 15 Jahre
SIC/NACE
56101

Eigentumsverhältnisse

Beneficial Owners
-
Mr Richard Armstrong

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
liquidation
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit: 2017-09-28
Letzte Einreichung: 2015-09-28
lezte Bilanzhinterlegung
2012-09-03
Jahresmeldung
Fälligkeit: 2019-09-17
Letzte Einreichung: 2018-09-03

PEOVER INNS LIMITED Firmenbeschreibung

PEOVER INNS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07007704. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.09.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2010 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Griffins Tavistock House South erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern PEOVER INNS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: Peover Inns Limited - Griffins Tavistock House South, Tavistock Square, London, WC1H 9LG, Grossbritannien

2009-09-03 15 Jahre
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • Jahre

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PEOVER INNS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-07-31) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-06-25) - 600

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-19) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-06-04) - LIQ02

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-07-22) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-leave-to-resign-liquidator (2020-07-22) - LIQ07

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-leave-to-resign-liquidator (2020-12-03) - LIQ07

    In den Warenkorb
     
  • cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-30) - PSC07

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-04) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-12) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-04-30) - TM02

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-30) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-01) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-01) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-30) - PSC01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-05) - 600

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-06-05) - LIQ01

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2019-06-05) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-06) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-04) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-06-09) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2018-05-22) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2017-11-28) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-23) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-22) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-06-28) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2016-09-09) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-29) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-11) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-23) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-06-30) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-26) - AA

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2015-05-09) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-06) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-06) - AP03

    In den Warenkorb
     
  • termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-06) - TM02

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-03-24) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2015-01-20) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2014-02-11) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-10) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsary (2013-10-01) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2013-11-13) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-21) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-28) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-10-03) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name (2011-09-06) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-15) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-15) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-02) - AA

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name (2011-09-06) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-08) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-current-extended (2010-11-29) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2009-09-03) - NEWINC

    In den Warenkorb
     
  • capital-allotment-shares (2009-12-16) - SH01

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2009-12-17) - MG01

    In den Warenkorb
     

expand_less