-
JUDGES CAPITAL LIMITED - 52c Borough High Street, London, SE1 1XN, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07003607
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 52c Borough High Street
- London
- SE1 1XN
- England 52c Borough High Street, London, SE1 1XN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CICUREL, David Elie
- LAVELLE, Mark Stephen
- ORMSBY, Bradley Leonard
- Prokuristen
- REECE, Glynn Carl
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.08.2009
- Alter der Firma 2009-08-28 14 Jahre
- SIC/NACE
- 28990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Judges Scientific Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 2138004H8LWNLOUB6E03
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-11
- Letzte Einreichung: 2023-08-28
-
JUDGES CAPITAL LIMITED Firmenbeschreibung
- JUDGES CAPITAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07003607. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 52C Borough High Street erreicht werden.
Jetzt sichern JUDGES CAPITAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Judges Capital Limited - 52c Borough High Street, London, SE1 1XN, England, Grossbritannien
- 2009-08-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JUDGES CAPITAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2022-01-24) - MR05
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-06-01) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-30) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-10-26) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-26) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-04) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-26) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-02) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-02) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-08-26) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-15) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-15) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-09-15) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-02) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-16) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-08-05) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-02) - MR01
-
resolution (2013-06-12) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-05-19) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-08-28) - NEWINC