-
HORN OF AFRICA AID - 147 Hunters Road, Birmingham, B19 1ES, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06994146
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 147 Hunters Road
- Birmingham
- B19 1ES
- England 147 Hunters Road, Birmingham, B19 1ES, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ABBAS, Abdulaziz Haji Ahmed
- HUSSAIN, Mustafa Haji Hassan
- MOHAMED, Mohamed Sheikh Ahmed
- MOHAMMAD, Abdirahman Sharif Hassan
- Prokuristen
- MOHAMED, Abdulkadir
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc-limited-exemption
- Gründungsdatum
- 19.08.2009
- Alter der Firma 2009-08-19 14 Jahre
- SIC/NACE
- 85600
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Abdulkadir Aden Mohamed
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-02
- Letzte Einreichung: 2021-08-19
-
HORN OF AFRICA AID Firmenbeschreibung
- HORN OF AFRICA AID ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc-limited-exemption registrierte Firma mit der Register-Nr. 06994146. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85600" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 01/01/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 147 Hunters Road erreicht werden.
Jetzt sichern HORN OF AFRICA AID HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Horn Of Africa Aid - 147 Hunters Road, Birmingham, B19 1ES, England, Grossbritannien
- 2009-08-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HORN OF AFRICA AID aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-12) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-01-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-25) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-08-25) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-07-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-04) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-11-06) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-04) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-05) - DISS40
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-20) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-08-20) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-19) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-19) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-07-04) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-31) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2014-08-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2013-09-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2012-09-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-03-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-08-24) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2011-08-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2010-12-06) - DS02
-
gazette-notice-voluntary (2010-11-23) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2010-11-10) - DS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2010-09-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-08-19) - NEWINC