-
CASTLEBRIDGE HOTELS GROUP LIMITED - 2 Chapel Court, Holly Walk, Leamington Spa, CV32 4YS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06991269
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Chapel Court
- Holly Walk
- Leamington Spa
- CV32 4YS
- England 2 Chapel Court, Holly Walk, Leamington Spa, CV32 4YS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BYRD, Christopher Richard
- CATTRELL, Alastair Kenneth
- DIENN, Jenna
- HALL, Simon William
- Prokuristen
- DIENN, Jenna
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.08.2009
- Alter der Firma 2009-08-14 14 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mrs Ruth Diana Claire Hudson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ZINNIA HOTELS GROUP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-18
- Letzte Einreichung: 2020-08-04
-
CASTLEBRIDGE HOTELS GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- CASTLEBRIDGE HOTELS GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06991269. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.08.2009 registriert. CASTLEBRIDGE HOTELS GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ZINNIA HOTELS GROUP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Chapel Court erreicht werden.
Jetzt sichern CASTLEBRIDGE HOTELS GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Castlebridge Hotels Group Limited - 2 Chapel Court, Holly Walk, Leamington Spa, CV32 4YS, Grossbritannien
- 2009-08-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CASTLEBRIDGE HOTELS GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-10) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-09-29) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-06) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-14) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-21) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-11-19) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-21) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-03) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-08-16) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-08-16) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-16) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-17) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-11-09) - MR04
-
change-sail-address-company-with-new-address (2018-12-11) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2018-12-11) - AD03
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-20) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-20) - PSC07
-
resolution (2017-11-21) - RESOLUTIONS
-
resolution (2017-11-08) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-04) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-09-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-19) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-19) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-30) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-08-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-15) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-08-15) - CH03
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-27) - AR01
-
legacy (2011-05-18) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-17) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-20) - 225
-
incorporation-company (2009-08-14) - NEWINC