-
FARNINGHAM BUTCHERS LIMITED - Owl Cottage High Street, Farningham, Dartford, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06984476
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Owl Cottage High Street
- Farningham
- Dartford
- Kent
- DA4 0DG Owl Cottage High Street, Farningham, Dartford, Kent, DA4 0DG UK
Management
- Geschäftsführung
- MAYATT, Gayle
- MAYATT, Timothy Stewart
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.08.2009
- Alter der Firma 2009-08-07 14 Jahre
- SIC/NACE
- 47220
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-08-21
- Letzte Einreichung: 2022-08-07
-
FARNINGHAM BUTCHERS LIMITED Firmenbeschreibung
- FARNINGHAM BUTCHERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06984476. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47220" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Owl Cottage High Street erreicht werden.
Jetzt sichern FARNINGHAM BUTCHERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Farningham Butchers Limited - Owl Cottage High Street, Farningham, Dartford, Kent, Grossbritannien
- 2009-08-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FARNINGHAM BUTCHERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-11-07) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2023-10-24) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-26) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-02-01) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-02) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-06-11) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-10) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-21) - GAZ1
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-15) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-13) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-10-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-12) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-13) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-11) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-11) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-05-28) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-27) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-07) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-05-03) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-01) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-01) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-01) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-11-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-08-07) - NEWINC