-
ENGLISH SPEECH AND PRONUNCIATION LIMITED - Fullers Wood Farthing Common, Lyminge, Folkestone, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06984318
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Fullers Wood Farthing Common
- Lyminge
- Folkestone
- Kent
- CT18 8DH Fullers Wood Farthing Common, Lyminge, Folkestone, Kent, CT18 8DH UK
Management
- Geschäftsführung
- GREENHALGH, Peter Andrew Livsey, Dr
- YARNOLD, Clare Elizabeth Jane Livsey
- Prokuristen
- GREENHALGH, Peter Andrew Livsey, Dr
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.08.2009
- Gelöscht am:
- 2020-02-18
- SIC/NACE
- 58110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Dr Peter Andrew Livsey Greenhalgh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-07
-
ENGLISH SPEECH AND PRONUNCIATION LIMITED Firmenbeschreibung
- ENGLISH SPEECH AND PRONUNCIATION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06984318. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Fullers Wood Farthing Common erreicht werden.
Jetzt sichern ENGLISH SPEECH AND PRONUNCIATION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: English Speech And Pronunciation Limited - Fullers Wood Farthing Common, Lyminge, Folkestone, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ENGLISH SPEECH AND PRONUNCIATION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-02-18) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-12) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-08) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-09-08) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-13) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-11) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-10-18) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-12-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-11) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-18) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-09-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-04) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-09-03) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-03) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-02) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-08-16) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-15) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2011-08-09) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-08-14) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-14) - CH01
-
legacy (2010-08-12) - 88(2)
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-16) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-08-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
resolution (2009-10-22) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-09-04) - 288a
-
resolution (2009-08-19) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-08-11) - 123
-
legacy (2009-08-11) - 287
-
legacy (2009-08-11) - 288b
-
incorporation-company (2009-08-07) - NEWINC