-
TAPPED AND PACKED LTD - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06964995
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Office D Beresford House
- Town Quay
- Southampton
- SO14 2AQ Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- GILL, Matthew Danby
- LOPEZ, Ashley Marie
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.07.2009
- Alter der Firma 2009-07-16 14 Jahre
- SIC/NACE
- 56102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Department Of Coffee And Social Affairs
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-15
- Letzte Einreichung: 2019-06-01
-
TAPPED AND PACKED LTD Firmenbeschreibung
- TAPPED AND PACKED LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06964995. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.07.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Office D Beresford House erreicht werden.
Jetzt sichern TAPPED AND PACKED LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tapped And Packed Ltd - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
- 2009-07-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TAPPED AND PACKED LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-05) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-02-15) - TM02
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-18) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-18) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-18) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-04) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-06) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-22) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-12) - AR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2013-08-12) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name (2013-08-12) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-25) - AR01
-
legacy (2012-09-20) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-04-21) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-02-16) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-19) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-07-19) - CH04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-03-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-07-16) - NEWINC