-
JUST PURE WATER LTD - 210 Mauretania Road, Nursling, Southampton, SO16 0YS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06959701
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 210 Mauretania Road
- Nursling
- Southampton
- SO16 0YS
- England 210 Mauretania Road, Nursling, Southampton, SO16 0YS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOLIDAY, Robin Gray
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.07.2009
- Gelöscht am:
- 2022-04-05
- SIC/NACE
- 36000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mt Nicholas Simpson
- -
- -
- Mr Robin Gray Holiday
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- PROJECT WEY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-07-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-15
- Letzte Einreichung: 2020-05-01
-
JUST PURE WATER LTD Firmenbeschreibung
- JUST PURE WATER LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06959701. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.07.2009 registriert. JUST PURE WATER LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PROJECT WEY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "36000" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.07.2014.Die Firma kann schriftlich über 210 Mauretania Road erreicht werden.
Jetzt sichern JUST PURE WATER LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Just Pure Water Ltd - 210 Mauretania Road, Nursling, Southampton, SO16 0YS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JUST PURE WATER LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
certificate-change-of-name-company (2020-10-27) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-14) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-07-28) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-07-28) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-30) - AD01
-
resolution (2019-09-10) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-22) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-01) - MR04
-
change-sail-address-company-with-new-address (2018-03-05) - AD02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-05) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC07
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2018-03-07) - AD03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-09) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-03) - AAMD
-
resolution (2017-05-24) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-08) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-11) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-28) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-30) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-12-23) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-21) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-12) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-11) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-21) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-14) - AR01
-
legacy (2011-02-25) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-12-18) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-26) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
certificate-change-of-name-company (2009-09-05) - CERTNM
-
incorporation-company (2009-07-11) - NEWINC