-
FEE PLAN LIMITED - 1 Nelson Street, Southend On Sea, Essex, SS1 1EG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06955214
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Nelson Street
- Southend On Sea
- Essex
- SS1 1EG
- England 1 Nelson Street, Southend On Sea, Essex, SS1 1EG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PONS, Francis Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.07.2009
- Gelöscht am:
- 2024-04-30
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Francis Joseph Pons
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- WILLIAMS JEFFREY BARBER JONES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-10-29
- Letzte Einreichung: 2018-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-21
- Letzte Einreichung: 2020-07-07
-
FEE PLAN LIMITED Firmenbeschreibung
- FEE PLAN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06955214. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.07.2009 registriert. FEE PLAN LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WILLIAMS JEFFREY BARBER JONES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 1 Nelson Street erreicht werden.
Jetzt sichern FEE PLAN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fee Plan Limited - 1 Nelson Street, Southend On Sea, Essex, SS1 1EG, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FEE PLAN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2022-01-08) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-11-19) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-11-30) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-21) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-21) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-07-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-19) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-25) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-25) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-07-31) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-10-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-21) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-21) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-22) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-07) - AP01
-
resolution (2016-11-16) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-13) - AD01
-
resolution (2016-06-01) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-04) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-01-28) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-13) - AD01
-
resolution (2016-05-31) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-29) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-24) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-04-30) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-28) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-06-01) - AA01
-
change-of-name-notice (2010-10-12) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-12) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2010-10-12) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-07-07) - NEWINC