-
LEA CROFT RESIDENTIAL LIMITED - Suite 122 33 Great George Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 3AJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06944811
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 122 33 Great George Street
- Leeds
- West Yorkshire
- LS1 3AJ Suite 122 33 Great George Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 3AJ UK
Management
- Geschäftsführung
- PEARCE, Mark
- Prokuristen
- PEARCE, Christine Ann
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.06.2009
- Gelöscht am:
- 2020-03-03
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Mark Pearce
- Mr Mark Pearce
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-08-30
-
LEA CROFT RESIDENTIAL LIMITED Firmenbeschreibung
- LEA CROFT RESIDENTIAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06944811. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 25.06.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite 122 33 Great George Street erreicht werden.
Jetzt sichern LEA CROFT RESIDENTIAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lea Croft Residential Limited - Suite 122 33 Great George Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 3AJ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LEA CROFT RESIDENTIAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-03-03) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-11) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-25) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2019-07-30) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-09-24) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-17) - GAZ1
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-09-25) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-14) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-04) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-05-29) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-09-04) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-13) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-09-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-05) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-06-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-11-29) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-02) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-28) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-15) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-28) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-23) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-08-16) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-24) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-28) - AR01
-
move-registers-to-sail-company (2010-07-28) - AD03
-
change-sail-address-company (2010-07-28) - AD02
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-03-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-06-25) - NEWINC