-
PROCESSMATRIX CONSULTING LTD - 71 Beckway Road, London, SW16 4HB, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06932932
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 71 Beckway Road
- London
- SW16 4HB
- England 71 Beckway Road, London, SW16 4HB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ASHONG, Kenneth Kofi
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.06.2009
- Alter der Firma 2009-06-12 14 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kenneth Kofi Ashong
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-21
- Letzte Einreichung: 2022-06-07
-
PROCESSMATRIX CONSULTING LTD Firmenbeschreibung
- PROCESSMATRIX CONSULTING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06932932. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.06.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 71 Beckway Road erreicht werden.
Jetzt sichern PROCESSMATRIX CONSULTING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Processmatrix Consulting Ltd - 71 Beckway Road, London, SW16 4HB, England, Grossbritannien
- 2009-06-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROCESSMATRIX CONSULTING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-08) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-03-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-13) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-24) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-07-08) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-07-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-13) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-21) - AD01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-07-20) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-06-12) - NEWINC
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-15) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-15) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-14) - CH01
-
legacy (2009-07-08) - 288a
-
legacy (2009-06-15) - 288b