-
EI2 LTD - Dawson House, 5 Jewry Street, London, EC3N 2EX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06883287
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Dawson House
- 5 Jewry Street
- London
- EC3N 2EX
- England Dawson House, 5 Jewry Street, London, EC3N 2EX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BOYDEN, Edmund John
- DAVALL, Richard John
- TROMBETTI, Lauren
- Prokuristen
- BOYDEN, Edmund John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.04.2009
- Alter der Firma 2009-04-21 15 Jahre
- SIC/NACE
- 46150
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard John Davall
- Mr Edmund John Boyden
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-10-31
- Letzte Einreichung: 2023-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-05
- Letzte Einreichung: 2024-04-21
-
EI2 LTD Firmenbeschreibung
- EI2 LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06883287. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.04.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46150" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Dawson House erreicht werden.
Jetzt sichern EI2 LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ei2 Ltd - Dawson House, 5 Jewry Street, London, EC3N 2EX, Grossbritannien
- 2009-04-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EI2 LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-04-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-04-24) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-24) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-05-25) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-10-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-10-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-10-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-05) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-07-19) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-27) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-08-15) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-26) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-02-28) - CH03
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-06-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-05-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-01-18) - AA
-
termination-director-company-with-name (2011-04-06) - TM01
-
capital-allotment-shares (2011-04-06) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-10) - AR01
-
legacy (2011-07-02) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-12-07) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-04-21) - NEWINC