-
PREVISION RESEARCH LIMITED - North House 2 Bond Estate, Bond Avenue, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06872763
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- North House 2 Bond Estate
- Bond Avenue
- Milton Keynes
- Buckinghamshire
- MK1 1SW North House 2 Bond Estate, Bond Avenue, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1SW UK
Management
- Geschäftsführung
- BAIRFELT, Stephen Jeffrey
- WILKINSON, Trevor
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.04.2009
- Alter der Firma 2009-04-07 15 Jahre
- SIC/NACE
- 73200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Martin Walls
- Mr Babar Ali Qureshi
- Mr Stephen Jeffrey Bairfelt
- Mr Trevor Wilkinson
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-05
- Letzte Einreichung: 2020-04-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-21
- Letzte Einreichung: 2021-04-07
-
PREVISION RESEARCH LIMITED Firmenbeschreibung
- PREVISION RESEARCH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06872763. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.04.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "73200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 05.04.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über North House 2 Bond Estate erreicht werden.
Jetzt sichern PREVISION RESEARCH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Prevision Research Limited - North House 2 Bond Estate, Bond Avenue, Milton Keynes, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2009-04-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PREVISION RESEARCH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-28) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-06) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-08) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-11) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-09) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-15) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-20) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-13) - AR01
-
resolution (2016-06-27) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-04-07) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-04-22) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-05-03) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-05-03) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-05) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-14) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-05-25) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-06) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-04-07) - NEWINC