-
BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY LTD - The Oakley, Kidderminster Road, Droitwich, Worcestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06859436
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Oakley
- Kidderminster Road
- Droitwich
- Worcestershire
- WR9 9AY
- United Kingdom The Oakley, Kidderminster Road, Droitwich, Worcestershire, WR9 9AY, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BERENS, Ulrich
- OWEN, Jeremy Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.03.2009
- Alter der Firma 2009-03-26 15 Jahre
- SIC/NACE
- 33190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Cb Chemie And Biotechnologie Ag
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AQUA-SOLV SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-03-11
- Letzte Einreichung: 2019-02-26
-
BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY LTD Firmenbeschreibung
- BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06859436. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.03.2009 registriert. BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AQUA-SOLV SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.02.2013.Die Firma kann schriftlich über The Oakley erreicht werden.
Jetzt sichern BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bio-Circle Surface Technology Ltd - The Oakley, Kidderminster Road, Droitwich, Worcestershire, Grossbritannien
- 2009-03-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-05) - PSC09
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-28) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-02-19) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-08) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-28) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-01) - AD01
-
resolution (2017-11-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-09-28) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-08) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-28) - PSC08
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-27) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-24) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-24) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-24) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-18) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-16) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-04-16) - CH03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-04-09) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-03-26) - NEWINC