-
UK REMEDIATION LTD - Unit 3b Greystoke Business Centre High Street, Portishead, Bristol, Somerset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06857817
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 3b Greystoke Business Centre High Street
- Portishead
- Bristol
- Somerset
- BS20 6PY
- England Unit 3b Greystoke Business Centre High Street, Portishead, Bristol, Somerset, BS20 6PY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DALTON, Richard John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.03.2009
- Alter der Firma 2009-03-25 15 Jahre
- SIC/NACE
- 39000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard John Dalton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-21
- Letzte Einreichung: 2021-04-07
-
UK REMEDIATION LTD Firmenbeschreibung
- UK REMEDIATION LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06857817. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.03.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "39000" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 3B Greystoke Business Centre High Street erreicht werden.
Jetzt sichern UK REMEDIATION LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Uk Remediation Ltd - Unit 3b Greystoke Business Centre High Street, Portishead, Bristol, Somerset, Grossbritannien
- 2009-03-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UK REMEDIATION LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-28) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-05-13) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-25) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-14) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-06-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-11) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-04-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-19) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-19) - AR01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2011-05-05) - RP04
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-04-19) - CH03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-12-13) - TM02
-
termination-secretary-company-with-name (2011-12-14) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-28) - AA
-
termination-director-company-with-name (2011-12-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-10-25) - AA
-
legacy (2010-05-12) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-05) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-08) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-04-08) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-17) - 288b
-
incorporation-company (2009-03-25) - NEWINC