-
STANHOPE UK LTD - Royal Sea Bathing, Canterbury Road, Margate, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06827233
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Royal Sea Bathing
- Canterbury Road
- Margate
- Kent
- CT9 5NT Royal Sea Bathing, Canterbury Road, Margate, Kent, CT9 5NT UK
Management
- Geschäftsführung
- HARRISS, Richard William
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.02.2009
- Alter der Firma 2009-02-23 15 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard William Harriss
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CORTON VILLAGE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-11-26
- Letzte Einreichung: 2019-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-29
- Letzte Einreichung: 2019-04-15
-
STANHOPE UK LTD Firmenbeschreibung
- STANHOPE UK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06827233. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.02.2009 registriert. STANHOPE UK LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CORTON VILLAGE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Royal Sea Bathing erreicht werden.
Jetzt sichern STANHOPE UK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stanhope Uk Ltd - Royal Sea Bathing, Canterbury Road, Margate, Kent, Grossbritannien
- 2009-02-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STANHOPE UK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-26) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-11-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-22) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-22) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-01) - AA01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-17) - AAMD
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-02-18) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-01) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-02) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-03) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-03) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-27) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-04-04) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2015-03-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-08) - AR01
-
legacy (2012-07-20) - MG01
-
legacy (2012-04-28) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-30) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-11-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-01-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-27) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-27) - AD01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2011-04-27) - AP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-28) - AR01
-
legacy (2011-09-09) - MG01
-
legacy (2011-11-08) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-11-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-08-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
termination-director-company-with-name (2009-12-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-10-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-10-29) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2009-08-25) - CERTNM
-
legacy (2009-08-18) - 287
-
legacy (2009-02-24) - 288b
-
incorporation-company (2009-02-23) - NEWINC