• UK
  • THE KNIFE THAT KILLED ME LIMITED - Highfield Grange Studios, Bubwith, Selby, YO8 6DP, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
06824230
Firmenstatus
EINGETRAGEN
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Highfield Grange Studios
Bubwith
Selby
YO8 6DP
England
Highfield Grange Studios, Bubwith, Selby, YO8 6DP, England UK

Management

Geschäftsführung
LATHAM, Alan Richard
MATTISON, Thomas Edward Jonathan
Prokuristen
LATHAM, Alan Richard

Firmendetails

Geschäftszweig
ltd
Gründungsdatum
19.02.2009
Alter der Firma
2009-02-19 15 Jahre
SIC/NACE
59111

Eigentumsverhältnisse

Beneficial Owners
Mr Alan Richard Latham

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
Active — Active proposal to strike off
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit: 2021-05-30
Letzte Einreichung: 2019-08-30
lezte Bilanzhinterlegung
2012-02-19
Jahresmeldung
Fälligkeit: 2023-03-05
Letzte Einreichung: 2022-02-19

THE KNIFE THAT KILLED ME LIMITED Firmenbeschreibung

THE KNIFE THAT KILLED ME LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06824230. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.02.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.02.2012.Die Firma kann schriftlich über Highfield Grange Studios erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern THE KNIFE THAT KILLED ME LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: The Knife That Killed Me Limited - Highfield Grange Studios, Bubwith, Selby, YO8 6DP, Grossbritannien

2009-02-19 15 Jahre
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • Jahre

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE KNIFE THAT KILLED ME LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • gazette-notice-compulsory (2023-08-22) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • dissolution-application-strike-off-company (2023-08-24) - DS01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-voluntary (2023-09-05) - GAZ1(A)

    In den Warenkorb
     
  • dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2023-09-12) - SOAS(A)

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-29) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2023-03-30) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-07) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2021-08-10) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-09-11) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-08-28) - AA

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-10) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-26) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-11) - AA

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-05) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2019-01-22) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-01-19) - AA

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2018-07-31) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-09-11) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2018-02-19) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-24) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2017-03-06) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-05-30) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2017-10-31) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-06) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-21) - AA

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-12-05) - AA

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2016-05-25) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2016-08-09) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2016-05-24) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-24) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-09-15) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-08) - DISS40

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2015-09-01) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-12-06) - AA

    In den Warenkorb
     
  • dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-10-22) - DISS16(SOAS)

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-02) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-person-secretary-company-with-change-date (2015-04-02) - CH03

    In den Warenkorb
     
  • change-person-director-company-with-change-date (2015-04-02) - CH01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-05) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-05) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-15) - AA

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-28) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name (2012-03-15) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • change-sail-address-company-with-old-address (2012-03-16) - AD02

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-16) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2012-06-01) - MG01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-11-29) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2012-05-02) - MG01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-11-24) - AA

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name (2011-10-31) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-07) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-sail-address-company (2010-04-12) - AD02

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-11-17) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-12) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • legacy (2009-02-20) - 288a

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2009-02-19) - NEWINC

    In den Warenkorb
     

expand_less