-
OPUS BUSINESS MEDIA LIMITED - Zurich House, Hulley Road, Macclesfield, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06786728
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Zurich House
- Hulley Road
- Macclesfield
- Cheshire
- SK10 2SF Zurich House, Hulley Road, Macclesfield, Cheshire, SK10 2SF UK
Management
- Geschäftsführung
- HANSON, Jeremy Mark
- WILKINSON, Hannah Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.01.2009
- Alter der Firma 2009-01-09 15 Jahre
- SIC/NACE
- 58142
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jeremy Mark Hanson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-20
- Letzte Einreichung: 2021-01-06
-
OPUS BUSINESS MEDIA LIMITED Firmenbeschreibung
- OPUS BUSINESS MEDIA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06786728. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.01.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58142" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Zurich House erreicht werden.
Jetzt sichern OPUS BUSINESS MEDIA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Opus Business Media Limited - Zurich House, Hulley Road, Macclesfield, Cheshire, Grossbritannien
- 2009-01-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OPUS BUSINESS MEDIA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-06) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-22) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-11) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-08) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-05) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-11) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-13) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-20) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-13) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-06) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-17) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-04-23) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-25) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-05-07) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-04-16) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-01-09) - SH08
-
resolution (2012-01-09) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-06) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-02) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-08) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-01-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-05-29) - 288a
-
incorporation-company (2009-01-09) - NEWINC
-
legacy (2009-08-11) - 395
-
legacy (2009-06-15) - 288a