-
BMV CONSTRUCTION SERVICES LIMITED - Telegraph House, 59 Wolverhampton Road, Stafford, ST17 4AW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06783770
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Telegraph House
- 59 Wolverhampton Road
- Stafford
- ST17 4AW Telegraph House, 59 Wolverhampton Road, Stafford, ST17 4AW UK
Management
- Geschäftsführung
- PRICE, Kenneth Raymond
- PRICE, Simon Kenneth
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.01.2009
- Gelöscht am:
- 2020-10-13
- SIC/NACE
- 43341
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kenneth Raymond Price
- Mr Simon Kenneth Price
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-20
- Letzte Einreichung: 2020-01-06
-
BMV CONSTRUCTION SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- BMV CONSTRUCTION SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06783770. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.01.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43341" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Telegraph House erreicht werden.
Jetzt sichern BMV CONSTRUCTION SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bmv Construction Services Limited - Telegraph House, 59 Wolverhampton Road, Stafford, ST17 4AW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BMV CONSTRUCTION SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-06-23) - GAZ1(A)
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-01-09) - PSC04
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-06-12) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-07) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-07) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-14) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-06) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-06) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-10) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-10) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-01) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-05-26) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-02) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-10) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-14) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-04-27) - AP03
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-10-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-01-22) - 88(2)
-
incorporation-company (2009-01-06) - NEWINC