-
CONSENSUS TECHNOLOGIES LIMITED - 40 Blythwood Road, Pinner, Middlesex, HA5 3QG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06771350
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 40 Blythwood Road
- Pinner
- Middlesex
- HA5 3QG
- England 40 Blythwood Road, Pinner, Middlesex, HA5 3QG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BHIMJIANI, Sailesh
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2008
- Alter der Firma 2008-12-11 15 Jahre
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Sailesh Bhimjiani
- Mr Sailesh Bhimjiani
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-14
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
-
CONSENSUS TECHNOLOGIES LIMITED Firmenbeschreibung
- CONSENSUS TECHNOLOGIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06771350. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 40 Blythwood Road erreicht werden.
Jetzt sichern CONSENSUS TECHNOLOGIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Consensus Technologies Limited - 40 Blythwood Road, Pinner, Middlesex, HA5 3QG, Grossbritannien
- 2008-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONSENSUS TECHNOLOGIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-12-14) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-19) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-10-20) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-15) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-07-10) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-01-03) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-07-02) - DISS40
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-08-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-13) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-15) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-18) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-31) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-12-31) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-09) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-02-09) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-08) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-01-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-05-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-10) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-02-10) - CH04
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-02-10) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-10-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-12-11) - NEWINC