-
PRESTON STREET LAUNDERETTE LTD - 291 Hangleton Road, Hove, BN3 7LR, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06769749
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 291 Hangleton Road
- Hove
- BN3 7LR
- England 291 Hangleton Road, Hove, BN3 7LR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- RAMIS, Nasrin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.12.2008
- Alter der Firma 2008-12-10 15 Jahre
- SIC/NACE
- 81210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Melat Ramis
- Nasrin Ramis
- -
- Nasrin Ramis
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2023-05-17
-
PRESTON STREET LAUNDERETTE LTD Firmenbeschreibung
- PRESTON STREET LAUNDERETTE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06769749. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.12.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "81210" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 291 Hangleton Road erreicht werden.
Jetzt sichern PRESTON STREET LAUNDERETTE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Preston Street Launderette Ltd - 291 Hangleton Road, Hove, BN3 7LR, England, Grossbritannien
- 2008-12-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRESTON STREET LAUNDERETTE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-19) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-19) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-19) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-19) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-29) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-03) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-03) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-09-05) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-21) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-08) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-15) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-05-08) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-11-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-15) - AA
-
termination-director-company-with-name (2010-04-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-11-13) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-21) - CH01
-
legacy (2009-03-19) - 288a
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-10) - 288b
-
incorporation-company (2008-12-10) - NEWINC