-
MILDMAY COBBETT LIMITED - HJS RECOVERY, 12-14 Carlton Place, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06750691
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- HJS RECOVERY
- 12-14 Carlton Place
- Southampton
- Hampshire
- SO15 2EA HJS RECOVERY, 12-14 Carlton Place, Southampton, Hampshire, SO15 2EA UK
Management
- Geschäftsführung
- CURRIE, Nohra
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.11.2008
- Gelöscht am:
- 2020-05-14
- SIC/NACE
- 47710
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-12-31
- Letzte Einreichung: 2012-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-12-01
- Letzte Einreichung:
-
MILDMAY COBBETT LIMITED Firmenbeschreibung
- MILDMAY COBBETT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06750691. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.11.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47710" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Hjs Recovery erreicht werden.
Jetzt sichern MILDMAY COBBETT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mildmay Cobbett Limited - HJS RECOVERY, 12-14 Carlton Place, Southampton, Hampshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MILDMAY COBBETT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-02-14) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-02-20) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-12-10) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-07-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-07-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-07-08) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-06-18) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-06-26) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-14) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2013-05-03) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2013-05-03) - 600
-
resolution (2013-05-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-28) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address (2012-11-28) - AD02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-04) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-03-23) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-25) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address (2011-11-25) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-25) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-12) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-01-01) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-14) - AR01
-
change-sail-address-company (2010-01-14) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-11-24) - AD01
-
legacy (2009-02-10) - 395
-
legacy (2009-02-05) - 395
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-11-17) - NEWINC