-
NCD AIRPORTS LIMITED - Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row, Birmingham, B3 2BB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06703036
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row
- Birmingham
- B3 2BB Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row, Birmingham, B3 2BB UK
Management
- Geschäftsführung
- DICKENS, Claire Louise
- Prokuristen
- DICKENS, Claire Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.09.2008
- Alter der Firma 2008-09-19 15 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Miss Claire Louise Dickens
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-05-31
- Letzte Einreichung: 2016-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-04-05
- Letzte Einreichung: 2017-03-22
-
NCD AIRPORTS LIMITED Firmenbeschreibung
- NCD AIRPORTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06703036. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.09.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row erreicht werden.
Jetzt sichern NCD AIRPORTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ncd Airports Limited - Bamfords Trust House 85-89 Colmore Row, Birmingham, B3 2BB, Grossbritannien
- 2008-09-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NCD AIRPORTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-02-08) - LIQ02
-
resolution (2018-01-23) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-15) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-01-09) - 600
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-03-12) - NDISC
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-29) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-22) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-23) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-03-22) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-01-04) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-26) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-02-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-04) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-10-04) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-13) - 287
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-19) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-11-30) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-12-03) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-11-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-25) - 225
-
legacy (2008-09-19) - 288a
-
legacy (2008-09-19) - 288b
-
incorporation-company (2008-09-19) - NEWINC