-
PENNAF PREMIER SALES & LETTINGS LTD - 1 Kings Avenue, London, N21 3NA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06697878
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Kings Avenue
- London
- N21 3NA 1 Kings Avenue, London, N21 3NA UK
Management
- Geschäftsführung
- BURNETT, Peter William
- TURNER, Stephen Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.09.2008
- Alter der Firma 2008-09-15 15 Jahre
- SIC/NACE
- 68310
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- PENNAF SALES & LETTINGS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-06-30
- Letzte Einreichung: 2015-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-09-29
- Letzte Einreichung: 2016-09-15
-
PENNAF PREMIER SALES & LETTINGS LTD Firmenbeschreibung
- PENNAF PREMIER SALES & LETTINGS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06697878. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.09.2008 registriert. PENNAF PREMIER SALES & LETTINGS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PENNAF SALES & LETTINGS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68310" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 1 Kings Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern PENNAF PREMIER SALES & LETTINGS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pennaf Premier Sales & Lettings Ltd - 1 Kings Avenue, London, N21 3NA, Grossbritannien
- 2008-09-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PENNAF PREMIER SALES & LETTINGS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-06-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-05-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-06-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-03) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-28) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-26) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-06-26) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-04-12) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-20) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2017-04-12) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-04-12) - 600
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-14) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-27) - AP01
-
change-of-name-notice (2010-08-03) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2010-08-03) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-12-23) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-23) - 288a
-
incorporation-company (2008-09-15) - NEWINC
-
legacy (2008-12-04) - 288b
-
certificate-change-of-name-company (2008-10-23) - CERTNM
-
legacy (2008-10-10) - 287