-
DURLSTONE PARTNERS LIMITED - 68 Ship Street, Brighton, East Sussex, BN1 1AE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06696628
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 68 Ship Street
- Brighton
- East Sussex
- BN1 1AE 68 Ship Street, Brighton, East Sussex, BN1 1AE UK
Management
- Geschäftsführung
- PUDDLE, James Gordon
- PUDDLE, Jane Dennistoun
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.09.2008
- Gelöscht am:
- 2023-06-16
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mrs Jane Dennistoun Puddle
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-26
- Letzte Einreichung: 2021-09-12
-
DURLSTONE PARTNERS LIMITED Firmenbeschreibung
- DURLSTONE PARTNERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06696628. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 12.09.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 68 Ship Street erreicht werden.
Jetzt sichern DURLSTONE PARTNERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Durlstone Partners Limited - 68 Ship Street, Brighton, East Sussex, BN1 1AE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DURLSTONE PARTNERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2023-03-16) - LIQ13
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-06-16) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2022-04-10) - LIQ01
-
resolution (2022-04-10) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-04-10) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-04-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-16) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-12) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-23) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-23) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-25) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-16) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-31) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-24) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-05-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2010-02-19) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-14) - 363a
-
legacy (2009-09-14) - 353
-
legacy (2009-03-17) - 88(2)
-
legacy (2009-05-18) - 88(2)
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-09-12) - NEWINC