-
DESIGNWERK UK LTD - CALCUTT MATTHEWS, 19 North Street, Ashford, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06665233
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- CALCUTT MATTHEWS
- 19 North Street
- Ashford
- Kent
- TN24 8LF CALCUTT MATTHEWS, 19 North Street, Ashford, Kent, TN24 8LF UK
Management
- Geschäftsführung
- COOK, Cristian James
- Prokuristen
- BACKHOUSE, Christopher
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.08.2008
- Alter der Firma 2008-08-05 15 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Cristian James Cook
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-04-30
- Letzte Einreichung: 2021-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-03-22
- Letzte Einreichung: 2022-03-08
-
DESIGNWERK UK LTD Firmenbeschreibung
- DESIGNWERK UK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06665233. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.08.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Calcutt Matthews erreicht werden.
Jetzt sichern DESIGNWERK UK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Designwerk Uk Ltd - CALCUTT MATTHEWS, 19 North Street, Ashford, Kent, Grossbritannien
- 2008-08-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DESIGNWERK UK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-15) - CS01
-
capital-cancellation-shares (2022-03-29) - SH06
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-05) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-03-08) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-13) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-15) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-01) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-04) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-01) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-28) - TM01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-03-09) - SH10
-
resolution (2016-03-09) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-09) - AA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-03-02) - SH10
-
capital-cancellation-shares (2016-03-02) - SH06
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-28) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-01-14) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-23) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-06-23) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-02) - AR01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2014-02-06) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-24) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-30) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-09-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-04-24) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-23) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-11) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2009-11-17) - AA01
-
legacy (2009-08-18) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-08-05) - NEWINC