-
VIKING MARINERS LIMITED - Norse Lodge. 2 Bearview, The Street. Eyke, Woodbridge, Suffolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06649114
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Norse Lodge. 2 Bearview
- The Street. Eyke
- Woodbridge
- Suffolk
- IP12 2QG Norse Lodge. 2 Bearview, The Street. Eyke, Woodbridge, Suffolk, IP12 2QG UK
Management
- Geschäftsführung
- CLARK, Susan Lorraine
- WEAVERS, Lee Martyn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.07.2008
- Alter der Firma 2008-07-17 15 Jahre
- SIC/NACE
- 50100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Lee Martyn Weavers
- Ms Susan Lorraine Clark
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-09
- Letzte Einreichung: 2020-08-26
-
VIKING MARINERS LIMITED Firmenbeschreibung
- VIKING MARINERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06649114. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.07.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "50100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Norse Lodge. 2 Bearview erreicht werden.
Jetzt sichern VIKING MARINERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Viking Mariners Limited - Norse Lodge. 2 Bearview, The Street. Eyke, Woodbridge, Suffolk, Grossbritannien
- 2008-07-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VIKING MARINERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-06-30) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-10-05) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-10-12) - GAZ1(A)
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-11-10) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-26) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-26) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-26) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-23) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-09-23) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-11-21) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-09-24) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-09) - 287
-
legacy (2009-09-14) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-07-17) - NEWINC