-
BRADLEY COURT PROPERTY LIMITED - Unit 1, Bradley Court Maple Road, Castle Donington, Derby, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06573983
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 1
- Bradley Court Maple Road
- Castle Donington
- Derby
- DE74 2UT Unit 1, Bradley Court Maple Road, Castle Donington, Derby, DE74 2UT UK
Management
- Geschäftsführung
- HIGGINS, Nicholas
- MCNICHOLAS, David Anthony
- OSMOND, Graham Peter
- SELLEY, Nicholas John
- Prokuristen
- MCNICHOLAS, David Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.04.2008
- Alter der Firma 2008-04-23 16 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Anthony Mcnicholas
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SILBURY 372 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-29
- Letzte Einreichung: 2020-04-15
-
BRADLEY COURT PROPERTY LIMITED Firmenbeschreibung
- BRADLEY COURT PROPERTY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06573983. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.04.2008 registriert. BRADLEY COURT PROPERTY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SILBURY 372 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 1 erreicht werden.
Jetzt sichern BRADLEY COURT PROPERTY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bradley Court Property Limited - Unit 1, Bradley Court Maple Road, Castle Donington, Derby, Grossbritannien
- 2008-04-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRADLEY COURT PROPERTY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-26) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-22) - PSC01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-05) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-04) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-02-03) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-02-08) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-16) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-03-09) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-05-20) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-04-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-04-11) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-05-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-03) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-03) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-20) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-04-20) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-17) - 363a
-
legacy (2009-04-17) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-06-11) - 288a
-
legacy (2008-06-11) - 288b
-
legacy (2008-06-19) - 287
-
certificate-change-of-name-company (2008-06-20) - CERTNM
-
legacy (2008-09-18) - 88(2)
-
legacy (2008-07-25) - 395
-
legacy (2008-07-26) - 395
-
resolution (2008-09-18) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2008-06-26) - MEM/ARTS
-
incorporation-company (2008-04-23) - NEWINC