-
A. & F. PILBEAM CONSTRUCTION LIMITED - Suite 2 2nd Floor Phoenix House, 32 West Street, Brighton, BN1 2RT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06571153
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 2 2nd Floor Phoenix House
- 32 West Street
- Brighton
- BN1 2RT Suite 2 2nd Floor Phoenix House, 32 West Street, Brighton, BN1 2RT UK
Management
- Geschäftsführung
- ARROW, Andrew John
- PILBEAM, Simon Philip
- CORBETT, Alan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.04.2008
- Alter der Firma 2008-04-21 16 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Philip Pilbeam
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-11-30
- Letzte Einreichung: 2022-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-05-03
- Letzte Einreichung: 2022-04-19
-
A. & F. PILBEAM CONSTRUCTION LIMITED Firmenbeschreibung
- A. & F. PILBEAM CONSTRUCTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06571153. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.04.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29/02/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite 2 2Nd Floor Phoenix House erreicht werden.
Jetzt sichern A. & F. PILBEAM CONSTRUCTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: A. & F. Pilbeam Construction Limited - Suite 2 2nd Floor Phoenix House, 32 West Street, Brighton, BN1 2RT, Grossbritannien
- 2008-04-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu A. & F. PILBEAM CONSTRUCTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
resolution (2023-02-17) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-02-17) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-02-17) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-02-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-06-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-24) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-07-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-01) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-02) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-10-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-08) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-11) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-23) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-04) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
second-filing-of-secretary-termination-with-name (2017-04-26) - RP04TM02
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-04-04) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-01) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-25) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-11-25) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-03-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-11-29) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-30) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-11-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-06) - AP01
-
legacy (2010-10-23) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-13) - 288a
-
legacy (2009-05-07) - 363a
-
legacy (2009-01-28) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-28) - 225
-
incorporation-company (2008-04-21) - NEWINC
-
legacy (2008-12-16) - 288b
-
legacy (2008-09-10) - 288a
-
legacy (2008-09-10) - 288b