-
TORBRIDGE VETERINARY HOSPITAL LIMITED - King Street House, 15 Upper King Street, Norwich, NR3 1RB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06568537
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- King Street House
- 15 Upper King Street
- Norwich
- NR3 1RB King Street House, 15 Upper King Street, Norwich, NR3 1RB UK
Management
- Geschäftsführung
- GILLIGAN, Richard
- PERRIN, Nicholas John
- Prokuristen
- GILLIGAN, Richard Aidan John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.04.2008
- Gelöscht am:
- 2019-06-08
- SIC/NACE
- 75000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Cvs (Uk) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-03-31
- Letzte Einreichung: 2016-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-17
-
TORBRIDGE VETERINARY HOSPITAL LIMITED Firmenbeschreibung
- TORBRIDGE VETERINARY HOSPITAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06568537. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.04.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "75000" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.04.2012.Die Firma kann schriftlich über King Street House erreicht werden.
Jetzt sichern TORBRIDGE VETERINARY HOSPITAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Torbridge Veterinary Hospital Limited - King Street House, 15 Upper King Street, Norwich, NR3 1RB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TORBRIDGE VETERINARY HOSPITAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
gazette-dissolved-liquidation (2019-06-08) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2019-03-08) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-04-13) - 600
-
resolution (2018-04-13) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-04-13) - LIQ01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-23) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-10) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-10) - AP03
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-03-07) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-07-08) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-30) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-05) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-30) - MR04
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-09-22) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-22) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-22) - AD01
-
resolution (2015-09-10) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-21) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-25) - AA
-
capital-cancellation-shares (2015-02-26) - SH06
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-13) - AAMD
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-return-purchase-own-shares (2014-05-20) - SH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-15) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-07-25) - MG04
-
legacy (2012-07-18) - MG04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-06) - AR01
-
legacy (2011-06-09) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-05-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-20) - 395
-
legacy (2009-08-06) - 395
-
legacy (2009-04-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-09-24) - AA
-
legacy (2008-09-24) - 225
-
incorporation-company (2008-04-17) - NEWINC